USA
Utah
Salt Lake
Sandy
van Patten, Eldon Lynn  b. 1919, d. 1993
van Patten, Eldon Lynn  b. 1919, d. 1993
Salt Lake County
Albrecht, Bula  b. 1923, d. 2004
Clayton, Marven Hardee  b. 1919, d. 2003
Hillyer, Leroy  d. 1896
Marshall, Gwendolyn  b. 1917, d. 2018
Poynter, Ruth M  b. 1902, d. 1994
van Patten, Eldon Lynn  b. 1919, d. 1993
van Patten, Eldon Lynn  b. 1919, d. 1993
Uintah
Wilson
Shatto, Floyd Lee  b. 1881, d. 1929
Utah
American Fork
Hunsaker, Miles Millard  b. 1896, d. 1974
Lehi
Hunsaker, Miles Millard  b. 1896, d. 1974
Provo
Kirkwood, John Alfred  b. 1873, d. 1950
Utah County
Kirkwood, John Alfred  b. 1873, d. 1950
Knight, Mae  b. circa 1875, d. 1912
Wayne
Fremont
Albrecht, Bula  b. 1923, d. 2004
Weber
Ogden
Glass, Victor Burin  b. 1918, d. 1994
Schamers, Sevilla  b. 1902, d. 1982
Utah Territory
Knight, Mae  b. circa 1875, d. 1912
Vermont
Armstrong, Cyrus  b. 1784, d. 1872
Atwood, Mary Elizabeth  b. 1845, d. 1915
Bliss, Frederick  b. 1764
Bourn, Isaac  b. circa 1781, d. 1853
Brewster, Alba  b. 1788
Brown, George W  b. circa 1801, d. 1875
Caldwell, Catherine  b. circa 1808, d. 1880
Clark, Abigail A  b. 1857
Colby, A J
Crafts, Dora L  b. 1884, d. 1918
Dewey, Zenas Coleman  b. 1801, d. 1867
Doane, Azubah  d. 1809
Doten, John Edward  b. 1780, d. 1863
Eastman, Flora R  d. before 1900
English, Ned Goodell  b. 1860, d. 1932
Haynes, Jemma  b. 1794, d. 1875
Heath, Jesse  d. 1839
Kimball, Isaiah Pratt  b. circa 1819, d. 1881
Livermore, Bathsheba  b. 1772, d. 1869
Morrill, Isaac  b. circa 1785, d. 1831
Page, Abiah  b. 1790, d. 1865
Page, Abigail  b. 1792, d. 1853
Page, Abraham  b. 1795, d. 1872
Page, Amos  b. 1799, d. 1799
Page, Betsey  b. 1788
Page, Caleb  b. 1787, d. 1822
Page, Eliza  b. 1804, d. 1884
Page, Ellen Tewksbury  b. 1851, d. 1903
Page, Isaiah Frost  b. 1851, d. 1911
Page, James  b. 1803
Page, John  b. 1772, d. 1846
Page, Josiah Kimball  b. 1776, d. 1862
Page, Nancy J  b. 1818, d. 1903
Page, Syntha  b. 1790
Pattee, Emma Jane  b. 1823, d. 1850
Pattee, Helen Marr  b. 1830, d. 1878
Pattee, Marion Frances  b. 1839, d. 1851
Pattee, Susan  b. circa 1834
Pike, William W  b. 1828, d. 1909
Pope, Mary  b. circa 1788, d. 1825
Powers, Joseph  b. 1809
Prescott, Joseph J  b. 1849
Sears, Silas  b. 1788, d. 1873
Sessions, Samuel H  b. 1828, d. 1905
Straw, Phoebe  d. 1842
Thomas, Deborah  b. 1785, d. circa 1862
Unknown, Roselle M  b. circa 1857
Willis, Meltiah S  b. circa 1839, d. 1906
Willson, Charles B  b. circa 1864, d. 1932
Wood, Lestina Lucy  b. circa 1816
Addison
Leicester
Cole, Hannah  b. 1792, d. 1829
Middlebury
Bennington
Bennington
Brownell, Ronald Melvin  b. 1914, d. 1993
Page, Ruth  b. 1717/18, d. 1796
Bennington Twp
Armstrong, Hezekiah  b. 1744, d. 1816
Haynes, Cynthia  b. 1791, d. 1859
Haynes, David  b. 1784
Haynes, Eunice  b. 1782
Haynes, Hannah  b. 1777
Haynes, Ira  b. 1779
Haynes, Jemma  b. 1794, d. 1875
Haynes, Lois  b. 1786
Haynes, Miriam  b. 1747, d. 1824
Haynes, Page  b. 1797
Haynes, Persis  b. 1788
Haynes, Ruth  b. 1775
Dorset
Armstrong, Candace  b. 1780, d. 1849
Armstrong, Cyrus  b. 1784, d. 1872
Armstrong, Hannah  b. 1781
Armstrong, Jonathan  b. 1743/44, d. 1826
Armstrong, Louis  b. 1787
Haynes, Abigail  b. 1751, d. 1825
Shaftsbury
Brewster, Alba  b. 1788
Bennington County
Armstrong, Hopestill  b. circa 1746, d. 1806
Bushley, Ephraim
Haynes, Cynthia  b. 1791, d. 1859
Haynes, David  b. 1749, d. 1813
Haynes, Jonathan  b. 1712, d. 1782
Haynes, Lydia  b. circa 1755, d. 1833
Hunt, Hannah  d. 1821
Rice, Alvah  b. 1794, d. 1847
Rice, Eunice  b. 1834
Rice, Harriet  b. 1837
Caledonia
Barnet
Carter, Judith
Dunn, John  b. 1798, d. 1873
Gleason, John Cloyes  b. 1874, d. 1939
Hitchcock, Stephen Washington  d. 1852
Johnson, William H  b. circa 1756, d. 1819
Laughlin, Claudie C  b. circa 1861, d. 1929
Page, Ellen Tewksbury  b. 1844, d. 1847
Page, Ezekiel Tewksbury  b. 1842, d. 1847
Page, Ezekiel Tewksbury  b. 1847, d. 1885
Page, Grace C  b. 1879, d. 1925
Page, Isaiah Frost  b. 1851, d. 1911
Page, Jacob  b. 1781
Page, Jennet  b. 1803, d. 1870
Page, Mary  b. 1772, d. 1827
Page, Moses  b. 1807, d. 1888
Page, Moses  b. circa 1850, d. 1898
Stevens, Sophia Candice  b. 1827, d. 1892
Tewksbury, Ellen Pecket  b. 1812, d. 1884
Burke
Atwood, Amelia Frances  b. 1839, d. 1840
Atwood, Emma Jane  b. 1847, d. 1863
Atwood, John Marshall  b. 1850, d. 1907
Atwood, Lydia Page  b. 1842, d. 1882
Danville
Chapman, Cynthia  b. 1794, d. 1875
Morrill, Isaac  b. circa 1785, d. 1831
Page, Martha  b. 1797, d. after 1870
Page, Nathan B  b. 1793, d. 1843
Pope, Mary  b. circa 1788, d. 1825
Powers, Daniel W  b. circa 1800, d. 1869
Groton
Frost, Betsey  b. circa 1818, d. 1886
Hosmer, Aaron  b. 1729, d. 1803
Merrill, Mercy
Page, Benjamin  b. 1814, d. 1897
Page, Enoch  b. 1751, d. 1805
Page, James  b. 1818, d. 1887
Page, John Straw  b. 1789, d. 1867
Page, William  b. 1821, d. 1888
Straw, Isabel  b. 1757, d. 1838
Wood, Lestina Lucy  b. circa 1816
Wormwood, Meribah  b. circa 1784, d. 1876
Groton Twp
Page, Isaiah Frost  b. 1851, d. 1911
Hardwick
Hutchins, Herbert OLiver  b. 1874, d. 1956
Page, Martha Sophia  b. 1879, d. 1960
Peacham
Blake, Ira  b. 1850, d. 1925
Blake, Isaac  b. 1822, d. 1905
Blanchard, Caroline  b. 1860, d. after 1940
Heath, Sarah  b. 1795, d. 1877
Ryegate
Boyce, Roselle M
Chamberlin, Amity  b. 1788, d. 1860
Cole, Hannah  b. 1792, d. 1829
Heath, Sarah  b. 1795, d. 1877
Hibbard, Dorcas  b. circa 1785, d. 1848
Hosmer, Rufus  b. 1770, d. 1834
Leonard, Henry M  b. 1846, d. 1907
Leonard, James Madison  b. 1840, d. 1877
Morrill, Isaac  b. circa 1785, d. 1831
Page, Abigail  b. 1774, d. 1860
Page, Abigail  b. 1805, d. 1862
Page, Abraham  b. 1795, d. 1872
Page, Betsey  b. 1795, d. 1875
Page, Helen  b. 1808, d. 1841
Page, Isaac  b. 1800, d. 1834
Page, Isaiah Frost  b. 1851, d. 1911
Page, Jennet  b. 1803, d. 1870
Page, Job  b. 1789, d. 1812
Page, John  b. 1778, d. 1799
Page, John  b. 1782, d. 1864
Page, John O  b. 1787, d. 1865
Page, Jonathan  b. 1770, d. 1831
Page, Josiah  b. 1748, d. 1814
Page, Josiah Kimball  b. 1776, d. 1862
Page, Martha  b. 1797, d. after 1870
Page, Mary  b. 1772, d. 1827
Page, Nathan B  b. 1793, d. 1843
Page, Nathan Barker  b. 1763, d. 1833
Page, Phebe  b. 1786
Page, Polly  b. 1792, d. 1852
Page, Sarah  b. 1778, d. 1871
Page, Sarah  b. 1780, d. 1796
Page, William  b. 1790, d. 1883
Page, William B  b. 1791, d. 1833
Wright, Benjamin  b. circa 1752, d. 1802
Ryegate Corner
Chamberlain, Louisa  b. 1751, d. 1835
Cole, Hannah  b. 1792, d. 1829
Dow, Abigail  b. 1765, d. 1823
Heath, Sarah  b. 1795, d. 1877
Johnson, Hugh  b. circa 1770, d. 1852
Page, Jacob  b. 1750, d. 1831
Page, Job  b. 1789, d. 1812
Page, John O  b. 1787, d. 1865
Page, Jonathan  b. 1770, d. 1831
Page, Josiah  b. 1748, d. 1814
Page, Nathan Barker  b. 1763, d. 1833
Page, William B  b. 1791, d. 1833
Wright, Benjamin  b. circa 1752, d. 1802
St Johnsbury
Farr, Caroline  b. 1843, d. 1929
Hutchins, Herbert OLiver  b. 1874, d. 1956
Otis, Charlotte Ann  b. 1869, d. 1957
Page, Benjamin Franklin (Dr)  b. 1843, d. 1917
Page, Caroline Elizabeth  b. 1876, d. 1956
Page, Childs Lang  b. 1860, d. 1885
Page, Ella Frances  b. 1872, d. 1884
Page, John M (Dr)  b. 1871, d. 1952
Page, Louis Samuel  b. 1874, d. 1883
Stannard
Hutchins, Herbert OLiver  b. 1874, d. 1956
West Groton
Page, John Straw  b. 1789, d. 1867
Wormwood, Meribah  b. circa 1784, d. 1876
Caledonia County
Dunn, John  b. 1798, d. 1873
Elmsley, Alexander  b. circa 1760, d. 1837
Page, Jennet  b. 1803, d. 1870
Stowe, Franklin Morgan  b. 1843, d. 1919
Caleonia County
Page, William B  b. 1791, d. 1833
Chittenden
Burlington
Chesley, Winnifred Lucy  b. 1878, d. 1966
Page, Benjamin Franklin (Dr)  b. 1843, d. 1917
Underhill
Bourn, Isaac  b. circa 1781, d. 1853
Page, Abiah  b. 1790, d. 1865
Sears, Silas  b. 1788, d. 1873
Essex
Canaan
Blais, Austin E  b. 1874, d. 1897
Blais, Edmond E  b. 1853, d. 1936
Blais, Mabel  b. 1896, d. 1969
Blais, Orrin E  b. 1879, d. 1898
Perry, Annette P  b. 1855, d. 1903
Perry, Jamon  b. 1843, d. 1926
Franklin
Bakersfield
Barber, Sarah Ann  b. 1823, d. 1908
Page, John Hale  b. 1807, d. 1888
Enosburg
Page, Maria  b. 1809, d. 1859
Enosburg Center
Page, Maria  b. 1809, d. 1859
Wheeler, Willard  b. 1800, d. 1882
Enosburgh
Campbell, Mary H  b. 1878, d. 1972
Chandler, Charles Scott  b. 1880, d. 1949
Fairfax
Maxfield, David  b. 1729, d. 1820
Fairfield
Sherman, Laura  b. 1811, d. 1842
Fletcher
Curtis, Merit  b. circa 1815, d. 1892
Georgia
Lewis, Harriet A  b. 1804, d. 1886
Page, Ansel  b. 1802, d. 1884
Page, Thomas  b. 1766, d. 1836
Sloan, Polly  b. 1778, d. 1864
Lamoille
Cambridge
Dustin, Abigail  b. 1766, d. 1814
Page, Aaron Doane  b. 1805
Page, Abiah  b. 1790, d. 1865
Page, Abigail  b. 1792, d. 1853
Page, Amos  b. 1788, d. 1791
Page, Amos  b. 1799, d. 1799
Page, Amos  b. 1804
Page, Ansel  b. 1802, d. 1884
Page, Anson  b. 1792
Page, David  b. 1794
Page, Elias Green (Rev)  b. 1801, d. 1857
Page, Eliza  b. 1804, d. 1884
Page, Eunice McFarland  b. 1802
Page, John  b. 1800
Page, John Hale  b. 1807, d. 1888
Page, Maria  b. 1809, d. 1859
Page, Mary  b. 1809, d. 1841
Page, Melinda  b. 1811
Page, Moses McFarland  b. 1797
Page, Patty  b. 1812, d. 1876
Page, Sally  b. 1796, d. 1813
Page, Samantha  b. 1794
Page, Syntha  b. 1790
Wetherby, Farwell  b. 1804, d. 1890
Wheeler, Willard  b. 1800, d. 1882
Hyde park
Fling, Rachel  b. 1812, d. 1869
Waterville
Barber, Sarah Ann  b. 1823, d. 1908
Caldwell, Catherine  b. circa 1808, d. 1880
Curtis, Merit  b. circa 1815, d. 1892
Livermore, Bathsheba  b. 1772, d. 1869
McFarland, Eunice  b. circa 1768, d. 1848
Morse, Maria  b. circa 1804, d. 1838
Page, Elias Green (Rev)  b. 1801, d. 1857
Page, John  b. 1772, d. 1846
Page, John Hale  b. 1807, d. 1888
Page, Parker  b. 1760, d. 1842
Page, Patty  b. 1812, d. 1876
Potter, Luke  b. 1827, d. 1911
Sherman, Laura  b. 1811, d. 1842
Lamoille County
Page, Sally  b. 1796, d. 1813
Orange
Bradford
Crafts, Dora L  b. 1884, d. 1918
Crafts, Florence K  b. 1879
Crafts, Pliny E  b. circa 1842, d. between 1910 and 1920
Kimball, Annette  b. 1846, d. 1925
Chelsea
Scales, Laura E  b. 1863, d. 1952
Corinth
Perry, Helen H  b. 1841, d. 1899
Willis, Ivan D  b. 1859, d. 1939
Willis, Meltiah S  b. circa 1839, d. 1906
East Thetford
Heaton, King Cyrus  b. 1798, d. 1859
Page, Abigail  b. 1805, d. 1862
Fairlee
Brown, George W  b. circa 1801, d. 1875
Page, Phebe  b. 1816, d. 1898
Prescott, Joseph J  b. 1849
Rugg, Moulton Edward  b. 1826, d. 1909
Newbury
Atwood, Mary Elizabeth  b. 1845, d. 1915
Bowles, Leonard  b. 1838
Bowles, Leonard  b. 1838
Chamberlain, Louisa  b. 1751, d. 1835
Chamberlain, Richard  b. 1714, d. 1784
Chamberlin, Amity  b. 1788, d. 1860
Elliott, Elizabeth  b. 1751, d. 1829
Fowler, Johnathan  b. circa 1766, d. 1852
Hosmer, Rufus  b. 1770, d. 1834
Johnson, Hugh  b. circa 1770, d. 1852
Johnson, Sarah  b. 1751, d. 1791
Page, Abigail  b. 1774, d. 1860
Page, Abigail  b. 1785
Page, Eunice  b. 1775, d. 1842
Page, Jacob  b. 1750, d. 1831
Page, Jacob  b. 1781
Page, John  b. 1778, d. 1799
Page, John O  b. 1787, d. 1865
Page, Ruth  b. 1783
Page, Sarah  b. 1776, d. 1777
Page, Sarah  b. 1778, d. 1871
Page, William  b. 1790, d. 1883
Randolph
Clark, Sarah Ann  b. 1811, d. 1889
Thetford
Clark, Sarah Ann  b. 1811, d. 1889
Heaton, King Cyrus  b. 1798, d. 1859
Page, Abigail  b. 1805, d. 1862
Page, Helen  b. 1808, d. 1841
Powers, Daniel W  b. circa 1799, d. 1869
Powers, Daniel W  b. circa 1800, d. 1869
Rugg, Moulton Edward  b. 1826, d. 1909
Thetford Center
Powers, Daniel W  b. circa 1800, d. 1869
Topsham
Frost, Betsey  b. circa 1818, d. 1886
Page, Benjamin  b. 1814, d. 1897
Washington
Crafts, Pliny E  b. circa 1842, d. between 1910 and 1920
Williamstown
Churchill, Artemas  b. 1797, d. 1873
Orange County
Rugg, Moulton Edward  b. 1826, d. 1909
Orleans
Coventry
Page, Abigail  b. 1792, d. 1853
Craftsbury
Hardy, Betsey  d. 1845
Derby
Grant, Maria Jane  b. 1862, d. 1945
Nourse, Martha Elizabeth  b. 1882, d. 1941
Whedon, William Henry  b. 1858, d. 1918
Newport
Westfield
Stone, Walter Weld  b. 1812, d. 1897
Rutland
East Poultney
Pattee, Phebe  b. 1818, d. 1874
Pattee, Savory D V  b. 1791, d. 1875
Pattee, William G  b. circa 1831, d. 1838
Searles, Louisa  b. circa 1793, d. 1860
Mount Holly
Hall, Eva Nancy  b. 1860, d. 1951
Priest, Ira A  b. 1856, d. 1933
Pawlet
Pattee, Seth  b. 1787, d. 1787
Poultney
Ames, Abigail  b. circa 1760, d. 1836
Pattee, Eliphalet  b. 1742, d. 1838
Pattee, Eliphalet  b. 1795, d. 1870
Pattee, Savory D V  b. 1791, d. 1875
Shrewsbury
Lamb, Serviah  b. circa 1756, d. 1844
Page, Phineas  b. 1755, d. 1813
Page, Phineas  b. 1778, d. 1821
Tinmouth
Hoadley, Jonathan  b. 1814, d. 1900
Wells
Pattee, Eliphalet  b. 1795, d. 1870
Pattee, Sarah  b. 1798
Pattee, Seth  b. 1793
Rutland County
Dunklee, James Eddie  b. 1888, d. 1945
Washington
Barre
Clark, Sarah Ann  b. 1811, d. 1889
Page, Abraham  b. 1795, d. 1872
Berlin
Dewey, Zenas Coleman  b. 1801, d. 1867
Page, Eliza  b. 1804, d. 1884
Berlin Corners
Dewey, Zenas Coleman  b. 1801, d. 1867
Page, Eliza  b. 1804, d. 1884
Cabot
Conner, Nathan  b. 1837, d. 1910
Calais
Bliss, Nancy  b. 1800, d. 1873
Marshfield
Conner, Ethel  b. 1867, d. before 1880
Conner, Mary L  b. 1869, d. 1925
Conner, Nathan  b. 1837, d. 1910
Page, Mary  b. 1843, d. 1930
Montpelier
Page, Benjamin Franklin (Dr)  b. 1843, d. 1917
Plainfield
Bancroft, Asa
Fuller, Rebecca  b. 1780, d. 1855
Page, Daniel Bodwell  b. 1779, d. 1828
Roxbury
Vaughn, Ida F  b. 1849, d. 1926
Windham
Brattleboro
North Vernon
Nesbitt, Robert William  b. 1878, d. 1912
Prescott, Hattie Belle  b. 1881, d. 1972
Vernon
Dunklee, James Eddie  b. 1888, d. 1945
Prescott, Daniel Page  b. 1853, d. 1918
Prescott, Frank Page  b. 1879, d. 1949
Prescott, Hattie Belle  b. 1881, d. 1972
Westminister
Page, Ernest Victor  b. 1902, d. 1978
Titus, Mary Priscilla  b. 1899
Windsor
Cavendish
Woodbury, Agustus Lee  b. 1818, d. 1818
Woodbury, Joseph Page  b. 1816, d. 1875
Woodbury, Seth Dodge  b. 1813, d. 1892
Hartland
Pattee, Rhoda  b. 1736, d. 1824
Ludlow
Page, Moses  b. 1753, d. 1838
Page, Moses F  b. 1819, d. 1895
Sargent, Sarah  b. 1755, d. 1838
Woodbury, Angeline Elizabeth  b. 1822, d. 1911
Woodbury, James Atkins  b. 1819, d. 1904
Woodbury, Relief Lorette  b. 1824
Norwich
Currier, Ebenezer  b. 1756, d. 1840
Quimby, Marcy  b. circa 1764, d. 1855
Pomfret
Doten, John Edward  b. 1780, d. 1863
Doten, Sarah Matilda  b. 1808
Page, Henry Little  b. 1801, d. 1844